Cargando...

Datos de UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA

UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA

 913822230   

www.unique.es
Objeto social

PONER A DISPOSICION DE OTRAS EMPRESAS USUARIAS, CON CARACTER TEMPORAL, TRABAJADORES CONTRATADOS.
CNAE 7810 - Actividades de las agencias de colocación

CIF

no disponible

Fecha constitución

-

Antigüedad

-

Capital social

-

Ventas

2.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

2008

Número empleados

2100

Consejo
Órgano administración

Administrador único

Otros datos de interés
Anteriormente denominada

SESA SAT ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA

Evolución de ventas


Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.


Ejercicio
Disponibilidad
Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

Filtrar por tipo de cargo:
EntidadRelaciónEntidad/RelaciónDesdeHasta
Sanchez Gutierrez Maria De La O Secr. No Consej. Sanchez Gutierrez Maria De La O
Secr. No Consej.
07/08/201316/01/2014
Martin Velayos Rodrigo Consej. Martin Velayos Rodrigo
Consej.
07/08/201316/01/2014
Martin Velayos Rodrigo Presid. Martin Velayos Rodrigo
Presid.
07/08/201316/01/2014
Beharel Francois-henri-leandre Consej. Beharel Francois-henri-leandre
Consej.
07/08/201316/01/2014
Beharel Francois-henri-leandre Vicepres. Beharel Francois-henri-leandre
Vicepres.
07/08/201316/01/2014
Van De Kraats Robert- Jan Consej. Van De Kraats Robert- Jan
Consej.
07/08/201316/01/2014
Beharel Francois-henri-leandre Apod. Beharel Francois-henri-leandre
Apod.
07/08/201316/01/2014
Van De Kraats Robert- Jan Apod. Van De Kraats Robert- Jan
Apod.
07/08/201316/01/2014
Martin Velayos Rodrigo Apod. Martin Velayos Rodrigo
Apod.
07/08/201316/01/2014
Requena Flores Ana Maria Apod. Requena Flores Ana Maria
Apod.
07/08/201316/01/2014
Carpizo Balsa Carlos Ignacio Apod. Carpizo Balsa Carlos Ignacio
Apod.
07/08/201316/01/2014
Larena Jimenez Raquel Apod. Larena Jimenez Raquel
Apod.
07/08/201316/01/2014
Leon Herranz Elizabeth Apod. Leon Herranz Elizabeth
Apod.
07/08/201316/01/2014
Ruiz Hernandez Antonio Luis Apod. Ruiz Hernandez Antonio Luis
Apod.
07/08/201316/01/2014
Menendez Gonzalez Juan Carlos Apod. Menendez Gonzalez Juan Carlos
Apod.
07/08/201316/01/2014
Yanes Rifaterra Graciela-maria Apod. Yanes Rifaterra Graciela-maria
Apod.
07/08/201316/01/2014
Carpintero Artiaga Maria Jose Apod. Carpintero Artiaga Maria Jose
Apod.
07/08/201316/01/2014
Miranda Garcia Diego Apod. Miranda Garcia Diego
Apod.
07/08/201316/01/2014
Guerrero Alcorlo Pedro Apod. Guerrero Alcorlo Pedro
Apod.
07/08/201316/01/2014
Del Hoyo Bilbao Maria Fatima Apod. Del Hoyo Bilbao Maria Fatima
Apod.
07/08/201316/01/2014
Parcel Esteban Pedro Apod. Parcel Esteban Pedro
Apod.
07/08/201316/01/2014
Diez Raimundez Concepcion Apod. Diez Raimundez Concepcion
Apod.
07/08/201316/01/2014
Moya Herreros Ivan Apod. Moya Herreros Ivan
Apod.
07/08/201316/01/2014
Sanchez Gutierrez Maria De La O Apod. Sanchez Gutierrez Maria De La O
Apod.
07/08/201316/01/2014
Molina Rua Carlos Apod. Molina Rua Carlos
Apod.
07/08/201316/01/2014
Gutierrez Gascon Rosa- Maria Apod. Gutierrez Gascon Rosa- Maria
Apod.
07/08/201316/01/2014
Viya Diez Maria-pilar Apod. Viya Diez Maria-pilar
Apod.
07/08/201316/01/2014
Caro Martinez Gloria Apod. Caro Martinez Gloria
Apod.
07/08/201316/01/2014
Lopez Luis Maria-teresa Apod. Lopez Luis Maria-teresa
Apod.
07/08/201316/01/2014
Diaz Estringana Diana Apod. Diaz Estringana Diana
Apod.
07/08/201316/01/2014
Ver más...

Vinculaciones

Vinculaciones societarias de UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SASESA SAT ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SASESA SAT ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SAUNIQUE PERSONAL  SLUNIQUE PERSONAL  SLSEDE MANAGEMENT CONSULTANCY SLSEDE MANAGEMENT CONSULTANCY SLSECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SASECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SASchreur Edwin Jacobus NicolaasSchreur Edwin Jacobus NicolaasSchreur Edwin Jacobus Nicolaas, Administrador Único de SESA SAT ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SASchreur Edwin Jacobus Nicolaas, Administrador Solidario de UNIQUE PERSONAL  SLSchreur Edwin Jacobus Nicolaas, Administrador Único,Socio Único de SEDE MANAGEMENT CONSULTANCY SLSchreur Edwin Jacobus Nicolaas, Consejero,Consejero Delegado de SECRETARY PLUS MANAGEMENT SUPPORT EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA o en los que participa indirectamente.


  • Otros conceptos:

    ESTA SOCIEDAD HA QUEDADO DISUELTA POR HABER SIDO ABSORBIDA POR LA SOCIEDAD "RANDSTAD EMPLEO EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA".
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/01/2014. Núm. 33657. T 30130, F 221, S 8, H M 216502, I/A 180 

    Disolución.

    Fusion.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/01/2014. Núm. 33657. T 30130, F 221, S 8, H M 216502, I/A 180 

    Extinción.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/01/2014. Núm. 33657. T 30130, F 221, S 8, H M 216502, I/A 180 
  • Anuncio de fusión y absorción

    En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, la "LME"), el accionista único de la Sociedad Absorbente y el accionista y socio único de las Sociedades Absorbidas han... Ver más

    Absorbente
    Absorbida
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 23/10/2013. Núm. A130060496.  
  • Revocaciones.

    Apoderado: AYUSO MANZANO JAVIER;ARCE SCARPATI SANTIAGO YAIR.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 08/10/2013. Núm. 443467. T 30130, F 219, S 8, H M 216502, I/A 179 

    Nombramientos.

    Apoderado: MOYA HERREROS IVAN.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 08/10/2013. Núm. 443467. T 30130, F 219, S 8, H M 216502, I/A 179 
  • Revocaciones.

    Apoderado: LAHOZ AZNAR MARIA GEMMA;FAGELLA GUILERA XAVIER.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/09/2013. Núm. 411554. T 30130, F 218, S 8, H M 216502, I/A 178 
  • Declaración de unipersonalidad.

    Cambio de identidad del socio único: RANDSTAD ESPAÑA SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 23/08/2013. Núm. 384261. T 30130, F 218, S 8, H M 216502, I/A 177 
  • Reelecciones.

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 08/08/2013. Núm. 366814. T 30130, F 218, S 8, H M 216502, I/A 176 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: DE JONG ANTOON FOKKO ERIC;ZANDBERGEN ROB. Presidente: DE JONG ANTOON FOKKO ERIC. Consejero: AYUSO MANZANO JAVIER. Cons.Del.Sol: AYUSO MANZANO JAVIER. Consejero: GONZALEZ LOPEZ JOSE RAMON. SecreNoConsj: GALAN MARTIN JOSE FERNANDO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 07/08/2013. Núm. 365314. T 30130, F 215, S 8, H M 216502, I/A 175 

    Nombramientos.

    SecreNoConsj: SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O. Consejero: MARTIN VELAYOS RODRIGO. Presidente: MARTIN VELAYOS RODRIGO. Consejero: BEHAREL FRANCOIS- HENRI-LEANDRE. Vicepresid.: BEHAREL FRANCOIS-HENRI-LEANDRE. Consejero: VAN DE KRAATS ROBERT-JAN. Apoderado: BEHAREL FRANCOIS-HENRI-LEANDRE;VAN DE KRAATS ROBERT-JAN;MARTIN VELAYOS RODRIGO;REQUENA FLORES ANA MARIA;CARPIZO BALSA CARLOS IGNACIO;LARENA JIMENEZ RAQUEL;LEON HERRANZ ELIZABETH;RUIZ HERNANDEZ ANTONIO LUIS;MENENDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS;YANES RIFATERRA GRACIELA MARIA;CARPINTERO ARTIAGA MARIA JOSE;MIRANDA GARCIA DIEGO;ARCE SCARPATI SANTIAGO YAIR;GUERRERO ALCORLO PEDRO;DEL HOYO BILBAO MARIA FATIMA;PARCEL ESTEBAN PEDRO;DIEZ RAIMUNDEZ CONCEPCION;MOYA HERREROS IVAN;SANCHEZ GUTIERREZ MARIA DE LA O;MOLINA RUA CARLOS;GUTIERREZ GASCON ROSA-MARIA;VIYA DIEZ MARIA-PILAR;CARO MARTINEZ GLORIA;LOPEZ LUIS MARIA-TERESA;DIAZ ESTRINGANA DIANA;VIOTA LOPEZ-LINARES RAFAEL;LAURI NAVARRO SANTIAGO;PEREZ PEREZ MANUEL;ECHEVARRIA MENDIGUREN JESUS;MALLOL MATEU CRISTINA;VALER MUNILLA MARTA;GARCIA-OLIAS JIMENEZ ANA;RIUS RADIGALES JORDI;MENENDEZ MARTINEZ ANDRES-FLORENTINO;LOIZAGA MAURIZ ALFREDO;GUTIERREZ GOMEZ OSCAR;LORENZO FERNANDEZ DANIEL PANCRACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 07/08/2013. Núm. 365314. T 30130, F 215, S 8, H M 216502, I/A 175 

    Cambio de domicilio social.

    C/ VIA DE LOS POBLADOS, 9 - EDIFICIO B, 5& PLANTA (MADRID).
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 07/08/2013. Núm. 365314. T 30130, F 215, S 8, H M 216502, I/A 175 
  • Revocaciones.

    Apoderado: LIZARRAGA MARIEZCURRENA ANA;MARCELO HERNANDEZ BEATRIZ;NOTARIO JURADO MARIA DOLORES;SAIZ GUZMAN EVA. Apo.Sol.: SAIZ GUZMAN EVA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/06/2013. Núm. 267125. T 30130, F 215, S 8, H M 216502, I/A 174 
  • Nombramientos.

    Apo.Sol.: LOBERA CIDON JOSE IGNACIO;ALVAREZ ROMAN LOURDES.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 27/05/2013. Núm. 253820. T 30130, F 213, S 8, H M 216502, I/A 171 

    Nombramientos.

    Apo.Sol.: BATALLA EDO ANNA;VEIGA VILAR MIRIAM;PERIS LLUESMA SONIA;RUEDA MARTINEZ CARMEN;GONZALEZ ARETXABALETA ELISABET.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 27/05/2013. Núm. 253821. T 30130, F 213, S 8, H M 216502, I/A 172 

    Nombramientos.

    Apo.Sol.: DE SIMONE EGIDO YOLANDA;GARCIA VICENTE ANA MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 27/05/2013. Núm. 253822. T 30130, F 214, S 8, H M 216502, I/A 173 
  • Revocaciones.

    Apoderado: SANCHEZ TORRECILLA JARA;MARTINEZ FERNANDEZ JUAN PABLO;SALA GARCIA NURIA;HERNANDEZ COUREL MONTAÑA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/02/2013. Núm. 64997. T 30130, F 212, S 8, H M 216502, I/A 170 
  • Nombramientos.

    Apoderado: RIUBROGENT MATAVACAS CRISTINA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/01/2013. Núm. 59776. T 30130, F 212, S 8, H M 216502, I/A 169 
  • Reelecciones.

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/12/2012. Núm. 534885. T 30130, F 212, S 8, H M 216502, I/A 168 
  • Nombramientos.

    Apo.Sol.: HOMS GIL MIREIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 05/11/2012. Núm. 477690. T 27943, F 215, S 8, H M 216502, I/A 166 

    Nombramientos.

    Apo.Sol.: NOCITO MUGICA JUAN.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 05/11/2012. Núm. 477691. T 27943, F 215, S 8, H M 216502, I/A 167 
  • Nombramientos.

    Apoderado: ESTEBAN ALONSO BEATRIZ.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/09/2012. Núm. 405682. T 27943, F 214, S 8, H M 216502, I/A 164 

    Nombramientos.

    Apo.Sol.: GALAN MARTIN JOSE FERNANDO;HERRERO SANZ MARIA DEL PILAR;SAIZ GUZMAN EVA;MARTINEZ MERINO ELENA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/09/2012. Núm. 405683. T 27943, F 215, S 8, H M 216502, I/A 165 
  • Nombramientos.

    Apoderado: RIVERO CANO RUBEN;GANDARA MAEZTU JORGE JUAN;SANCHEZ CONDE ILDEFONSO;GONZALEZ DEL YERRO MEDINA JESUS;SERRANO SOLDADO ANTONIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/05/2012. Núm. 224788. T 27943, F 211, S 8, H M 216502, I/A 161 

    Nombramientos.

    Apoderado: GALAN MARTIN JOSE FERNANDO;HERRERO SANZ MARIA DEL PILAR;SAIZ GUZMAN EVA;MARTINEZ MERINO ELENA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/05/2012. Núm. 224789. T 27943, F 212, S 8, H M 216502, I/A 162 

    Nombramientos.

    Apoderado: MENENDEZ LOPEZ MONICA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/05/2012. Núm. 224790. T 27943, F 213, S 8, H M 216502, I/A 163 
  • Revocaciones.

    Apoderado: DE LA CRUZ MARTIN ROMO MIGUEL ANGEL;MENDIBE GIL LEIRE;SOLER SEGUI MARIA ISABEL;PUEBLA PASTOR SONIA;HURTADO NAZCO GILBERTO;SALA ALBERT RAIMUNDO JOSE;MULAS FUERTES LUIS ALFREDO;QUINTERO RODRIGUEZ LAURA. Apo.Sol.: MARTINEZ PAREDES CELIA;PERALTA MIÑANA ARMANDO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/04/2012. Núm. 171272. T 27943, F 210, S 8, H M 216502, I/A 158 

    Otros conceptos:

    AMPLIADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DOÑA ESTHER BRAVO ALARCOS.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/04/2012. Núm. 171273. T 27943, F 211, S 8, H M 216502, I/A 159 

    Otros conceptos:

    AMPLIADO EL PODER CONFERIDO A FAVOR DE DOÑA ANGELES BULLON MARIN.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/04/2012. Núm. 171274. T 27943, F 211, S 8, H M 216502, I/A 160 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: SCHREUR EDWIN JACOBUS NICOLAAS. Con.Delegado: SCHREUR EDWIN JACOBUS NICOLAAS.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 09/03/2012. Núm. 136007. T 27943, F 210, S 8, H M 216502, I/A 157 

    Nombramientos.

    Consejero: AYUSO MANZANO JAVIER. Cons.Del.Sol: AYUSO MANZANO JAVIER. Consejero: GONZALEZ LOPEZ JOSE RAMON.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 09/03/2012. Núm. 136007. T 27943, F 210, S 8, H M 216502, I/A 157 

Informes comerciales Axesor

Informe axesor 360ºInforme de CréditoPerfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Básica
Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentes
Solo dirigentes
Empresas relacionadas
(accionistas, participadas,…)
Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)No incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Completo
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Extracto
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Completo
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Extracto
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
AccederAccederAcceder

UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA anteriormente denominada SESA SAT ESPAÑA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA es una empresa inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Actividades de las agencias de colocación.

La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.

UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA tiene 26 cargos directivos en activo y 341 cargos directivos históricos.

La empresa está auditada por PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.