La cobertura a los socios, sean personas físicas o jurídicas, de los riesgos asegurados mediante una prima fija pagadera al comienzo del período del riesgo.
Información sobre balances y cuentas de resultados de DIVINA PASTORA SEGUROS MUTUA DE SEGUROS depositados en el Registro Mercantil de en los últimos ejercicios.
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por DIVINA PASTORA SEGUROS MUTUA DE SEGUROS o en los que participa indirectamente.
Aparece en el envio 169 del año 2023. Publicado en el Boletín 182 de fecha 22/09/23 y referencia 04113312023. se publico por error. Ya que cese ya constaba inscrito.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 15/09/2023. Núm. 424669. T 11148, L 8426, F 155, S 8, H V 13700, I/A 223
Ceses/Dimisiones.
Consejero: MORENO MARQUEZ JOSE VICENTE;ABARCA TORRALBA MARIA CARMEN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 15/09/2023. Núm. 411331. T 11148, L 8426, F 155, S 8, H V 13700, I/A 223
Reelecciones.
Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL. Auditor: ERNST & YOUNG SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 15/09/2023. Núm. 411331. T 11148, L 8426, F 155, S 8, H V 13700, I/A 223
Revocaciones.
Apo.Sol.: JIMENEZ GUARDIA FRANCISCO JAVIER. Apoderado: PENAS SANTOS JOSE LUIS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 08/08/2023. Núm. 369284. T 11148, L 8426, F 155, S 8, H V 13700, I/A 222
Nombramientos.
Consejero: CARRACEDO GARNATEO PATRICIA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 22/05/2023. Núm. 247969. T 11148, L 8426, F 154, S 8, H V 13700, I/A 220
Modificaciones estatutarias.
Modificar el Artículo 26 de los Estatutos Sociales.. Modificar la redacción del Artículo 19 de los Estatutos..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2023. Núm. 109816. T 11148, L 8426, F 153, S 8, H V 13700, I/A 218
Ceses/Dimisiones.
Consejero: DE BAGO RUIZ LUIS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 23/02/2023. Núm. 109817. T 11148, L 8426, F 154, S 8, H V 13700, I/A 219
Reelecciones.
SecreNoConsj: LOPEZ CATALA IGNACIO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 19/01/2023. Núm. 45373. T 11148, L 8426, F 153, S 8, H V 13700, I/A 217
Reelecciones.
Auditor: ERNST & YOUNG SL. Aud.C.Con.: ERNST & YOUNG SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 03/08/2022. Núm. 374589. T 11148, L 8426, F 153, S 8, H V 13700, I/A 216
Nombramientos.
Apoderado: PENAS SANTOS JOSE LUIS.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/05/2022. Núm. 265718. T 11148, L 8426, F 152, S 8, H V 13700, I/A 213
Nombramientos.
Apoderado: BROTONS NAVARRO DIEGO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/05/2022. Núm. 265719. T 11148, L 8426, F 152, S 8, H V 13700, I/A 214
Nombramientos.
Apoderado: TORRE ROS JAVIER.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/05/2022. Núm. 265720. T 11148, L 8426, F 152, S 8, H V 13700, I/A 215
Ceses/Dimisiones.
Dir. General: NIETO RANERO ARMANDO MIGUEL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/05/2022. Núm. 214463. T 11148, L 8426, F 151, S 8, H V 13700, I/A 211
Revocaciones.
Apoderado: NIETO RANERO ARMANDO MIGUEL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/05/2022. Núm. 214463. T 11148, L 8426, F 151, S 8, H V 13700, I/A 211
Revocaciones.
Apoderado: JIMENEZ GUARDIA FRANCISCO JAVIER.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/05/2022. Núm. 214464. T 11148, L 8426, F 152, S 8, H V 13700, I/A 212
Nombramientos.
Apo.Sol.: JIMENEZ GUARDIA FRANCISCO JAVIER.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/05/2022. Núm. 214464. T 11148, L 8426, F 152, S 8, H V 13700, I/A 212
Revocaciones.
Apoderado: JORDA SAMPER JUAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/04/2022. Núm. 190964. T 11148, L 8426, F 150, S 8, H V 13700, I/A 205
Nombramientos.
Apo.Sol.: JORDA SAMPER JUAN.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/04/2022. Núm. 190964. T 11148, L 8426, F 150, S 8, H V 13700, I/A 205
Revocaciones.
Apoderado: MORENO MARQUEZ JOSE VICENTE. Apo.Sol.: MORENO MARQUEZ JOSE VICENTE.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/04/2022. Núm. 190965. T 11148, L 8426, F 150, S 8, H V 13700, I/A 206
Nombramientos.
Apo.Sol.: MORENO MARQUEZ JOSE VICENTE.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 21/04/2022. Núm. 190965. T 11148, L 8426, F 150, S 8, H V 13700, I/A 206