Cargando...

Datos de NH EUROPA SL

NH EUROPA SL

 934914890     934110790

Objeto social

CNAE 5510 - Hoteles y alojamientos similares

CIF

B59354258

Fecha constitución

28/06/1990

Antigüedad

34 años

Capital social

100.372.905,00 €

Ventas

0.5M €

Registro

Barcelona

Últimas cuentas depositadas

2021

Consejo
Auditor

DELOITTE SL



Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de NH EUROPA SL depositados en el Registro Mercantil de Barcelona en los últimos ejercicios.


Ejercicio
Disponibilidad
2018
Inmediata
2019
Inmediata
2020
Inmediata
2021
Inmediata
Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

EntidadRelaciónEntidad/RelaciónDesdeHasta
Fernandez-marcote Castrillejo Manuel-cesar Apod. Mancom. Fernandez-marcote Castrillejo Manuel-cesar
Apod. Mancom.
25/04/2014
Cascales Dones Eduardo Apod. Mancom. Cascales Dones Eduardo
Apod. Mancom.
25/04/2014
Garcia Salmones Fernandez Jose Felix Apod. Mancom. Garcia Salmones Fernandez Jose Felix
Apod. Mancom.
25/04/2014

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por NH EUROPA SL o en los que participa indirectamente.

Mostrar Filtros

  • Nombramientos.

    Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;MUÑOZ SANCHEZ ANA-ISABEL;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BRUFAU ROTES CARMEN;BELSA GIL MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/03/2024. Núm. 156747. T 33226, F 98, S 8, H M 597946, I/A 20 
  • Revocaciones.

    Apo.Manc.: LARREA DIAZ DIEGO PAULO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/10/2023. Núm. 458985. T 33226, F 98, S 8, H M 597946, I/A 19 
  • Revocaciones.

    Apoderado: MORA NARVAEZ JUAN;GALLEGO PEREZ MANUELA;CHOLLET IBARRA ROBERTO;RODRIGUEZ GUTIERREZ ANTONIO;PRIM VIDAL JOSE;PEREZ GARCIA ANGEL;BATLE DOMENECH FRANCISCA;LOPEZ FELIU MARIA ROSA CANELA;PRECIADOS FERNANDEZ JOSE ANGEL;PEREZ GARCIA ANGEL;JOHER FERRAN JAVIER;BENET BERENGUE DOMINGO;PEREZ GARCIA ANGEL;MORATAL ABEIJON ELENA MARIA;PIZCUETA MATEU JAVIER;CAMPILLO MIRANDA PEDRO;SERRA SANCHEZ JULIO MANUEL;ALARCON HORNOS JOSE MARIA;GARCIA DE VINUESA DIEGO;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;GUTIERREZ FERNANDEZ ERNESTO;PEREZ GARCIA ANGEL;SOLA MARTINEZ JOAQUIN RAMON;SAEZ HERRERO GASPAR;ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO IGNACIO;CHOLLET IBARRA ROBERTO;DE RUEDA KORTEN WANDA;AGUILERA NAVARRO ISABEL MARIA;DE MORA NARVAEZ JUAN;BENET BERENGUE DOMINGO;MATOSES GARCIA- VALDES FERNANDA;DE LA PEÑA ROBLES ALMUDENA;BASTERRECHEA ALVAREZ JOSE MARIA;COSTA PEREZ MARIBEL;JOHER FERRAN JAVIER;LEON HONRUBIA CRISTINA;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;COMPANY SALA DIEGO;MIGALLON RODRIGUEZ AROA;ANSO MAINZ ANGEL MARIA;GARCIA VINUESA DIEGO;ROBLES MONTERO JOSE ANTONIO;BASTERRECHEA ALVAREZ JOSE MARIA;ROCA LOPEZ SUSANA;MORENO BAENA MARIA MAR;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;ALARCON HORNOS JOSE MARIA;CONEJERO MARTINEZ ALBERTO;DIAZ PETISCO ALMUDENA;CASADO GARCIA MANUEL;COSTA PEREZ MARIBEL;BASTERRECHEA ALVAREZ JOSE MARIA;CENZANO GUTIERREZ CARMEN;MORENO BAENA MARIA DEL MAR;CAMPOS VILLADRE FELIPE;MARCHANTE RODRIGUEZ JUAN MANUEL;BARROSO BARROSO EMILIA;GRAU BAGA SARA;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;MARTI BINUE ALBERTO;RIERA PIDEMUNT RICARDO;MALO RUIZ BELEN;ULLAN CALVO ANGEL;BASTERRECHEA ALVAREZ JOSE MARIA;MELENCHON PEREZ MANUEL;CAMPILLO MIRANDA PEDRO;MORATAL ABEIJON ELENA;SANCHO MESTRE MARIA JESUS;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;UREÑA MARTINEZ ALFONSO;SERRA SANCHEZ JULIO;TRIVIÑO GONZALEZ GEMA;MARTINEZ ABELLAN JULIA;MARTINEZ DE LOS REYES NIETO RAQUEL;BASTERRECHEA ALVAREZ JOSE MARIA;GARCIA DE VINUESA GONZALEZ DIEGO;GARCIA QUINTANA MARIA JOSE;PEREZ RODRIGUEZ CESAR;HERNANDEZ GARCIA MANUEL;MURO AGUILAR LETICIA;PAMO MARTIN MARIA ADORACION;ALARCON HORNOS JOSE MARIA;CONEJERO MARTINEZ ALBERTO;DIAZ PETISCO ALMUDENA;CASADO GARCIA MANUEL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/11/2022. Núm. 535485. T 33226, F 97, S 8, H M 597946, I/A 18 
  • Reelecciones.

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 18/10/2022. Núm. 467932. T 33226, F 97, S 8, H M 597946, I/A 17 
  • Revocaciones.

    Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;CASCALES DONES EDUARDO;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX. Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BELSA GIL MARIA;MORILLO VERA FRANCISCO JOSE.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/05/2021. Núm. 247559. T 33226, F 97, S 8, H M 597946, I/A 16 

    Nombramientos.

    Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS;LARREA DIAZ DIEGO PAULO;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BRUFAU ROTES CARMEN;BELSA GIL MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/05/2021. Núm. 247559. T 33226, F 97, S 8, H M 597946, I/A 16 
  • Revocaciones.

    Apo.Manc.: PUENTE FERRERAS BEATRIZ;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BELSA GIL MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 02/12/2020. Núm. 436656. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 15 

    Nombramientos.

    Apoderado: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BELSA GIL MARIA;MORILLO VERA FRANCISCO JOSE.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 02/12/2020. Núm. 436656. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 15 
  • Ceses/Dimisiones.

    Adm. Solid.: PUENTE FERRERAS BEATRIZ.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/09/2020. Núm. 315965. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 14 

    Nombramientos.

    Adm. Solid.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/09/2020. Núm. 315965. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 14 
  • Revocaciones.

    Apoderado: PUENTE FERRERAS BEATRIZ;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX;CEBADA ROLDAN FERNANDO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 12/02/2020. Núm. 76926. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 13 

    Nombramientos.

    Apo.Manc.: PUENTE FERRERAS BEATRIZ;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX;CEBADA ROLDAN FERNANDO;BELSA GIL MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 12/02/2020. Núm. 76926. T 33226, F 96, S 8, H M 597946, I/A 13 
  • Nombramientos.

    Auditor: PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/08/2019. Núm. 373851. T 33226, F 95, S 8, H M 597946, I/A 12 
  • Reelecciones.

    Auditor: DELOITTE SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/09/2018. Núm. 391481. T 33226, F 95, S 8, H M 597946, I/A 11 
  • Reelecciones.

    Auditor: DELOITTE SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/10/2017. Núm. 425545. T 33226, F 95, S 8, H M 597946, I/A 9 

    Nombramientos.

    Apoderado: PUENTE FERRERAS BEATRIZ;MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX;CEBADA ROLDAN FERNANDO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/10/2017. Núm. 425546. T 33226, F 95, S 8, H M 597946, I/A 10 
  • Ceses/Dimisiones.

    Adm. Solid.: ARANGUREN GONZALEZ-TARRIO JESUS IGNACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/08/2017. Núm. 331957. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 8 

    Nombramientos.

    Adm. Solid.: LAHOZ MALPARTIDA LAIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/08/2017. Núm. 331957. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 8 
  • Reelecciones.

    Auditor: DELOITTE SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/09/2016. Núm. 383677. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 7 
  • Revocaciones.

    Apo.Manc.: GARCIA ANDRES JOSE-MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/06/2016. Núm. 273438. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 6 

    Nombramientos.

    Apo.Manc.: MARTINEZ JURADO LUIS MIGUEL;CASCALES DONES EDUARDO;GARCIA SALMONES FERNANDEZ JOSE FELIX.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/06/2016. Núm. 273438. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 6 
  • Ceses/Dimisiones.

    Adm. Solid.: CHOLLET IBARRA ROBERTO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/05/2016. Núm. 230843. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 5 

    Nombramientos.

    Adm. Solid.: PUENTE FERRERAS BEATRIZ.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 24/05/2016. Núm. 230843. T 33226, F 94, S 8, H M 597946, I/A 5 
  • Reelecciones.

    Auditor: DELOITTE SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/11/2015. Núm. 463262. T 33226, F 93, S 8, H M 597946, I/A 4 
  • Revocaciones.

    Apoderado: FERNANDEZ-MARCOTE CASTRILLEJO MANUEL-CESAR.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 06/03/2015. Núm. 116230. T 33226, F 93, S 8, H M 597946, I/A 3 

    Nombramientos.

    Apo.Manc.: GARCIA ANDRES JOSE-MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 06/03/2015. Núm. 116230. T 33226, F 93, S 8, H M 597946, I/A 3 
  • Cambio de domicilio social.

    C/ SANTA ENGRACIA 120 (MADRID).
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 04/03/2015. Núm. 107955. T 33226, F 93, S 8, H M 597946, I/A 2 
  • Ampliación de capital.

    Capital: 370.000,00 Euros. Resultante Suscrito: 100.742.905,00 Euros.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 07/01/2015. Núm. 12935. T 42833, F 194, S 8, H B 9716, I/A 84 
  • Nombramientos.

    Con fecha 10 de octubre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de como Auditor de la sociedad.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/10/2014. Núm. 420185. T 42833, F 194, S 8, H B 9716, I/A 83 
  • Nombramientos.

    Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:

    Apoderados Mancomunados
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 25/04/2014. Núm. 189094. T 42833, F 194, S 8, H B 9716, I/A 82 
  • Ampliación de capital.

    Con fecha 19 de marzo de 2014, mediante la correspondiente escritura ha quedado incrito en el Registro Mercantil la ampliación de 56.828.778 € del capital social de la empresa. Esta ampliación representa un 315.96 % de incremento del capital, quedando un capital social resultante de 74.814.628€.

    Capital social anterior:17.985.850 €
    Aumento de capital:56.828.778 €
    Capital social resultante:74.814.628 €
    % incremento:315.96 %
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/03/2014. Núm. 137252. T 42833, F 193, S 8, H B 9716, I/A 80 

Informes comerciales Axesor

Informe axesor 360ºInforme de CréditoPerfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Básica
Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentes
Solo dirigentes
Empresas relacionadas
(accionistas, participadas,…)
Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)No incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Completo
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Extracto
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Completo
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Extracto
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
AccederAccederAcceder

NH EUROPA SL inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Su clasificación nacional de actividades económicas es Hoteles y alojamientos similares.

capital social de la empresa es de 100.372.905,00 euros y tiene una facturación anual inferior a 500.000 euros.

NH EUROPA SL tiene 3 cargos directivos en activo y 0 cargos directivos históricos.

La empresa está auditada por DELOITTE SL.