Cargando...

Datos de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL

LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL

 915079697 915079697  

CTRA VILLAVERDE A VALLECAS, KM. 3,5 Km (MADRID). Ver mapa

www.lactalisfoodservice.es
Objeto social

SE AMPLIA A. LA COMPRA, HIGIENIZACION Y ESTERILIZACION DE LA LECHE Y LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS LACTEOS Y OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y BEBIDAS ASI COMO LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION,
CNAE 4633 - Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles

CIF

no disponible

Fecha constitución

11/08/1999

Antigüedad

25 años

Capital social

-

Ventas

2.5M €

Registro

Madrid

Últimas cuentas depositadas

2021

Número empleados

89

Consejo
Otros datos de interés
Anteriormente denominada

GRUPO EL PRADO CERVERA SL, LACTALIS RESTAURACION SL

Evolución de ventas


Balances y cuentas de resultados

Información sobre balances y cuentas de resultados de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL depositados en el Registro Mercantil de Madrid en los últimos ejercicios.


Ejercicio
Disponibilidad
2018
Inmediata
2019
Inmediata
2020
Inmediata
2021
Inmediata
Consultar en Axesor
Consultar en Axesor

Cargos y representantes

EntidadRelaciónEntidad/RelaciónDesdeHasta
Belloch Cortes Raul Secr. No Consej. Belloch Cortes Raul
Secr. No Consej.
10/01/2012
Antuña Rodriguez Aurelio Consej. Antuña Rodriguez Aurelio
Consej.
10/01/2012
Vejux Laurent Consej. Vejux Laurent
Consej.
10/01/2012
Antuña Rodriguez Aurelio Presid. Antuña Rodriguez Aurelio
Presid.
10/01/2012
Antuña Rodriguez Aurelio Consej. Del. Antuña Rodriguez Aurelio
Consej. Del.
10/01/2012
B S A INTERNATIONAL SA Consej. B S A INTERNATIONAL SA
Consej.
05/01/201010/01/2012
Jaouen Daniel Marie Consej. Jaouen Daniel Marie
Consej.
05/01/201010/01/2012
Jaouen Daniel Marie Presid. Jaouen Daniel Marie
Presid.
05/01/201010/01/2012
Peslier Michel Secr. Peslier Michel
Secr.
19/12/200810/01/2012
Meziere Joseph Gilles Consej. Del. Meziere Joseph Gilles
Consej. Del.
10/01/2012
Meziere Joseph Gilles Consej. Meziere Joseph Gilles
Consej.
10/01/2012
Besnier Emmanuel Represent. Besnier Emmanuel
Represent.
10/01/2012
Gomez Ruiz Daniel Apod. Mancom. Gomez Ruiz Daniel
Apod. Mancom.
24/08/2011
Blanch Sanfederico Luis Apod. Mancom. Blanch Sanfederico Luis
Apod. Mancom.
24/08/2011
Leonard Michel Consej. Leonard Michel
Consej.
05/01/201020/05/2010
Ruiz Calavera Maria Dolores Apod. Ruiz Calavera Maria Dolores
Apod.
13/01/2010
Jaouen Daniel Consej. Jaouen Daniel
Consej.
05/01/2010
Jaouen Daniel Presid. Jaouen Daniel
Presid.
05/01/2010
Vejux Laurent Apod. Vejux Laurent
Apod.
18/02/2009
Peslier Michel Consej. Peslier Michel
Consej.
19/12/2008
Levantal Thierry Consej. Levantal Thierry
Consej.
19/12/2008
Levantal Thierry Secr. Levantal Thierry
Secr.
19/12/2008

Vinculaciones

Vinculaciones societarias de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SLLACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLLACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLEL CASTILLO LACTALIS  SLEL CASTILLO LACTALIS  SLINDUSTRIAS LACTEAS VALLISOLETANAS SLINDUSTRIAS LACTEAS VALLISOLETANAS SLGRUPO LACTALIS IBERIA SAGRUPO LACTALIS IBERIA SALACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SLLACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SLLACTALIS LOGISTICA SLLACTALIS LOGISTICA SLINDUSTRIAS LACTEAS DE PEÑAFIEL SLINDUSTRIAS LACTEAS DE PEÑAFIEL SLLACTALIS ZAMORA SLLACTALIS ZAMORA SLLECHE DE GALICIA SLLECHE DE GALICIA SLFORLACTARIA OPERADORES LECHEROS SAFORLACTARIA OPERADORES LECHEROS SAPeslier MichelPeslier MichelVejux LaurentVejux LaurentAntuña Rodriguez AurelioAntuña Rodriguez AurelioBelloch Cortes RaulBelloch Cortes RaulPeslier Michel, Consejero de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLVejux Laurent, Consejero de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLAntuña Rodriguez Aurelio, Presidente,Consejero,Consejero Delegado de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLBelloch Cortes Raul, Secretario No Consejero de LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA  SLAntuña Rodriguez Aurelio, Consejero,Presidente de EL CASTILLO LACTALIS  SLVejux Laurent, Consejero de INDUSTRIAS LACTEAS VALLISOLETANAS SLPeslier Michel, Consejero de GRUPO LACTALIS IBERIA SAVejux Laurent, Consejero de GRUPO LACTALIS IBERIA SAAntuña Rodriguez Aurelio, Consejero,Consejero Delegado de GRUPO LACTALIS IBERIA SAPeslier Michel, Consejero de LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SLVejux Laurent, Consejero de LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SLAntuña Rodriguez Aurelio, Presidente,Consejero Delegado,Consejero de LACTALIS COMPRAS Y SUMINISTROS SLVejux Laurent, Consejero de LACTALIS LOGISTICA SLAntuña Rodriguez Aurelio, Consejero Delegado,Presidente,Consejero de LACTALIS LOGISTICA SLBelloch Cortes Raul, Secretario No Consejero de LACTALIS LOGISTICA SLVejux Laurent, Consejero de INDUSTRIAS LACTEAS DE PEÑAFIEL SLAntuña Rodriguez Aurelio, Consejero Delegado,Presidente,Consejero de INDUSTRIAS LACTEAS DE PEÑAFIEL SLBelloch Cortes Raul, Secretario No Consejero de INDUSTRIAS LACTEAS DE PEÑAFIEL SLVejux Laurent, Consejero de LACTALIS ZAMORA SLAntuña Rodriguez Aurelio, Presidente,Consejero Delegado,Consejero de LACTALIS ZAMORA SLBelloch Cortes Raul, Secretario No Consejero de LACTALIS ZAMORA SLPeslier Michel, Consejero de LECHE DE GALICIA SLVejux Laurent, Consejero de LECHE DE GALICIA SLVejux Laurent, Consejero de FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS SAAntuña Rodriguez Aurelio, Presidente,Consejero de FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS SA

Productos, Marcas y Nombres Comerciales

EL PRADO
VerMarca vigente
PURLAIT
VerMarca caducada
PROLAIT
VerMarca caducada
VITALAC
VerMarca vigente
BIO CHOLECK
VerMarca caducada
VICENTETA
VerMarca vigente
PRODUCTOS VERGE
VerMarca vigente
HORCHATA VERGE
VerMarca vigente
LATEL
VerMarca vigente

Anuncios en boletines oficiales

Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL o en los que participa indirectamente.

Mostrar Filtros
Mostrar Filtros

  • Reelecciones.

    Auditor: MAZARS AUDITORES SLP.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 26/01/2024. Núm. 57969. T 35601, F 170, S 8, H M 321048, I/A 44 
  • Nombramientos.

    Apo.Man.Soli: SIMON SACRISTAN MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/06/2023. Núm. 393212. T 35601, F 169, S 8, H M 321048, I/A 43 

    Fe de erratas:

    Se omitió publicar en la inscripción 43 el nombramiento de SIMON SACRISTAN MARIA como apoderado mancomunado y solidario.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/06/2023. Núm. 393212. T 35601, F 169, S 8, H M 321048, I/A 43 
  • Revocaciones.

    Apoderado: BELLOCH CORTES RAUL;BELLOCH CORTES RAUL;BELLOCH CORTES RAUL;BELLOCH CORTES RAUL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/06/2023. Núm. 306084. T 35601, F 169, S 8, H M 321048, I/A 43 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA. Secretario: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/03/2023. Núm. 165775. T 35601, F 168, S 8, H M 321048, I/A 42 

    Nombramientos.

    SecreNoConsj: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA. Consejero: ROUX-BLANC CATHERINE ELISABETH RAYMONDE.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 29/03/2023. Núm. 165775. T 35601, F 168, S 8, H M 321048, I/A 42 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO. Presidente: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO. Con.Delegado: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/12/2022. Núm. 565964. T 35601, F 168, S 8, H M 321048, I/A 41 

    Nombramientos.

    Consejero: GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN. Presidente: GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN. Con.Delegado: GALINDO GIMENEZ BORJA JUAN.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 19/12/2022. Núm. 565964. T 35601, F 168, S 8, H M 321048, I/A 41 
  • Revocaciones.

    Apoderado: GUILLES MEZIERE JOSEPH;MEZIERE JOSEPH GILLES;TAHON JEAN PIERRE FERDINAND;MARTIN RUIZ MARIA JOSE;BLANCH SAN FEDERICO LUIS MARCELINO;MARTIN RUIZ MARIA JOSE. Apo.Manc.: BLANCH SAN FEDERICO LUIS MARCELINO;GOMEZ RUIZ DANIEL. Apoderado: VEJUX LAURENT;DURAN GARCIA ANA MARIA;VEJUX LAURENT;RUIZ CALAVERA MARIA DOLORES. Apo.Manc.: GOMEZ RUIZ DANIEL;BLANCH SANFEDERICO LUIS. Apo.Man.Soli: LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA. Apoderado: LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 10/10/2022. Núm. 456053. T 35601, F 167, S 8, H M 321048, I/A 40 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA. SecreNoConsj: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/08/2022. Núm. 367300. T 35601, F 167, S 8, H M 321048, I/A 39 

    Nombramientos.

    Consejero: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA. Secretario: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 01/08/2022. Núm. 367300. T 35601, F 167, S 8, H M 321048, I/A 39 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO. Presidente: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO. Cons.Del.Sol: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO. Consejero: GUEDES RIBEIRO ODETE-MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/02/2022. Núm. 90895. T 35601, F 166, S 8, H M 321048, I/A 38 

    Nombramientos.

    Consejero: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO;LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA. Presidente: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO. Con.Delegado: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 22/02/2022. Núm. 90895. T 35601, F 166, S 8, H M 321048, I/A 38 
  • Nombramientos.

    Auditor: MAZARS AUDITORES SLP.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 13/10/2020. Núm. 354599. T 35601, F 166, S 8, H M 321048, I/A 37 
  • Reelecciones.

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 03/12/2019. Núm. 510882. T 35601, F 166, S 8, H M 321048, I/A 36 
  • Nombramientos.

    Apoderado: BELLOCH CORTES RAUL;CLIMENT CRUZ BEATRIZ;COBIAN LAREO MARIA ANTONIA;PEREZ PEREZ ANGEL RAMON.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/10/2019. Núm. 435844. T 35601, F 165, S 8, H M 321048, I/A 35 
  • Revocaciones.

    Apoderado: LOPEZ MEDINA DAVID.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/07/2019. Núm. 323875. T 35601, F 164, S 8, H M 321048, I/A 34 

    Otros conceptos:

    Se revocan los poderes conferidos a D. LAURENT VEJUX, en las escrituras de fechas 20/11/ 2007, n. 2842 y de 27/01/ 2009, n. 187, que causaron las inscripciones 7ª y 11ª, respectivamente, de traslado. Se revoca el poder a Doña ANA DURAN "GARCIA", en escritura de fecha 20/11/2007, n. 2843, que causo la inscripción 8ª de traslado, y el conferido a Doña MARIA DOLORES RUIZ CALAVERA, en escritura de fecha 15/12/2009, número 2691, que causó la inscripción 14ª de traslado.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/07/2019. Núm. 323875. T 35601, F 164, S 8, H M 321048, I/A 34 
  • Ceses/Dimisiones.

    SecreNoConsj: LOPEZ MEDINA DAVID.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 26/11/2018. Núm. 485455. T 35601, F 164, S 8, H M 321048, I/A 33 

    Nombramientos.

    SecreNoConsj: COBIAN LAREO MARIA ANTONIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 26/11/2018. Núm. 485455. T 35601, F 164, S 8, H M 321048, I/A 33 
  • Nombramientos.

    Apoderado: LOPEZ MEDINA DAVID;BELLOCH CORTES RAUL;PEREZ PEREZ ANGEL RAMON;COBIAN LAREO MARIA ANTONIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/05/2018. Núm. 218165. T 35601, F 163, S 8, H M 321048, I/A 30 

    Nombramientos.

    Apoderado: ORTEGA VIELBA MARTA;LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/05/2018. Núm. 218166. T 35601, F 163, S 8, H M 321048, I/A 31 

    Cambio de domicilio social.

    C/ JUAN DE MARIANA, 17 B. (MADRID).
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 14/05/2018. Núm. 218167. T 35601, F 164, S 8, H M 321048, I/A 32 

    Revocaciones.

    Apoderado: TAHON JEAN PIERRE FERDINAND;MARTIN RUIZ MARIA JOSE;BLANCH SAN FEDERICO LUIS MARCELINO;MARTIN RUIZ MARIA JOSE;SANTANA RUIZ ZORRILLA NAYRA. Apo.Manc.: BLANCH SAN FEDERICO LUIS MARCELINO;GOMEZ RUIZ DANIEL;SANTANA RUIZ ZORRILLA NAYRA;BELLOCH CORTES RAUL. Apoderado: MOLERES VIDAL JUAN IGNACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 16/05/2018. Núm. 218168. T 35601, F 163, S 8, H M 321048, I/A 29 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: MICHOT CHRISTINE.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/03/2018. Núm. 144731. T 35601, F 162, S 8, H M 321048, I/A 28 

    Nombramientos.

    Consejero: GUEDES RIBEIRO ODETE-MARIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/03/2018. Núm. 144731. T 35601, F 162, S 8, H M 321048, I/A 28 
  • Ceses/Dimisiones.

    Consejero: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO. Presidente: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO. Con.Delegado: ELOLA ZARAGUETA IGNACIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/10/2017. Núm. 420331. T 35601, F 162, S 8, H M 321048, I/A 27 

    Nombramientos.

    Consejero: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO. Presidente: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO. Cons.Del.Sol: QUINTANA RODRIGUEZ ANTONIO.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 17/10/2017. Núm. 420331. T 35601, F 162, S 8, H M 321048, I/A 27 
  • Nombramientos.

    Apo.Man.Soli: LOPEZ FRAILE MARIA NATALIA.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 20/07/2017. Núm. 309651. T 35601, F 161, S 8, H M 321048, I/A 26 
  • Modificaciones estatutarias.

    Refundidos los estatutos sociales..
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 21/03/2017. Núm. 143717. T 21811, F 89, S 8, H M 321048, I/A 25 
  • Nombramientos.

    Auditor: ERNST & YOUNG SL.
    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil 
    Fecha inscripción: 18/08/2016. Núm. 355061. T 21811, F 89, S 8, H M 321048, I/A 24 

Informes comerciales Axesor

Informe axesor 360ºInforme de CréditoPerfil Comercial de Empresa
Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleadosIncluye Importe de ventas y número de empleados
Información mercantil y comercialIncluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Completa
Incluye Información mercantil y comercial
Básica
Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentesIncluye Administradores y dirigentes
Solo dirigentes
Empresas relacionadas
(accionistas, participadas,…)
Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)Incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)No incluye Empresas relacionadas (accionistas, participadas,…)
Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pagoIncluye Categoría crediticia y probabilidad de incumplimiento de pago
Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judicialesIncluye Impagos (RAI y Asnef Empresas) e incidencias judiciales
Balance y cuenta de pérdidas y gananciasIncluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Completo
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Extracto
Incluye Balance y cuenta de pérdidas y ganancias
Ratios y magnitudes económico-financierasIncluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Completo
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Extracto
Incluye Ratios y magnitudes económico-financieras
Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadasIncluye Representación gráfica de empresas relacionadas
Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sectorIncluye Comparativa del balance con la media del sector
Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio netoIncluye Estado de flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio neto
Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avalesIncluye Fuentes de financiación y avales
Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcasIncluye Subvenciones, concursos/subastas públicas y marcas
AccederAccederAcceder

LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL anteriormente denominada GRUPO EL PRADO CERVERA SL, LACTALIS RESTAURACION SL inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Su clasificación nacional de actividades económicas es Comercio al por mayor de productos lácteos, huevos, aceites y grasas comestibles.

La empresa tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.

LACTALIS FOOD SERVICE IBERIA SL tiene 10 cargos directivos en activo y 11 cargos directivos históricos.

La empresa está auditada por BDO AUDITORES SL.