TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE MERCANCIAS POR CUALQUIER MEDIO (YA SEA AEREO, NAVAL O TERRESTRE), CONSIGNACION, DEPOSITO, EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO DE LAS CITADAS MERCANCIAS, SERVICIO DE MENSAJERIA ASI COMO TODA C CNAE 5229 - Otras actividades anexas al transporte
Resumen cronológico de actos publicados en las ediciones digitales de Boletines Oficiales (BORME, BOE, BOPI) inscritos por ACCIONA FORWARDING SA o en los que participa indirectamente.
Revocaciones.
Apoderado: MARTINEZ DE GUINEA LUIS. Apo.Sol.: CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL;HIDALGO CAMPOS JUAN;CRUZ PALACIOS JUAN MANUEL;HIDALGO CAMPOS JUAN;VEGA-PENICHET LOPEZ JORGE;DE SANTAMARIA DE PAREDES CASTILLO VICENTE;FIGUEROA GOMEZ DE SALAZAR JOSE JULIO;FERNANDEZ-VILLAVERDE GUTIERREZ RAIMUNDO;FERRAN HUETE IGNACIO;JUAN GARCIA MARIA SOLEDAD. Apo.Man.Soli: MARTIN OVIEDO MERITXELL. Apo.Sol.: ALCANTARA DELGADO AYALA CARMEN GEMA. Apo.Man.Soli: MOLINA OLTRA RICARDO;RODRIGUEZ BORGES TOMAS. Apoderado: FERNANDEZ LOPEZ MARIA PILAR;ZABALA ORROÑO MAITE;LOPEZ PRADES INMACULADA;VAZQUEZ MORENO SANDRA;BARRIENTOS SERANTES JOSE ANTONIO;LOPEZ GONGORA EUGENIO;ORTIZ DE VIGON MARTINEZ DE LEJARDA MAURICIO;MORILLO VAZQUEZ ALBERTO;GIRONES BAS JOSE. Apo.Sol.: ALBES GOMEZ RAFAEL. Apo.Manc.: ROMAN REIMONDEZ HELENA;DE MIGUEL HURTADO MARIA ISABEL. Apoderado: VILLAMUERA FERNANDEZ ISABEL;ACIN LISA DELFIN IGNACIO. Apo.Man.Soli: POVEDANO JIMENEZ JUAN MANUEL;OLAIZOLA DIAZ JORGE MARCOS. Apo.Sol.: RAMIREZ OCHOA RAQUEL;CRESPO SASTRE FRANCISCO. Apo.Man.Soli: JIMENEZ SERRANO RAMON;LLORENS COMBALIA JACOBO;PAEZ INDACO SOLEDAD. Apoderado: DE LA NATIVIDAD ESCUDERO JAVIER;DE LAS HERAS VELASCO NURIA;DE LAS HERAS VELASCO NURIA. Apo.Manc.: RODRIGUEZ BORGES TOMAS. Apo.Man.Soli: HERAS VELASCO NURIA. Apo.Sol.: ALONSO TORRES LAURA;NUÑEZ FREIRE VICTORIO MANUEL;LOPEZ LOPEZ JUAN CARLOS;VAZQUEZ MAYOR CRISTINA;GARCIA ALVAREZ BENILDE;MARTINEZ MARTINEZ MONICA;SANCHEZ DEL VALLE ENRIQUE;BARTOLOME ALEGRIA WILMA;SEBASTIA SANCHO JUAN RAMON;GONZALEZ MEDINA MARTA;SALVAT FILOMENO DANIEL;ELIZALDE GUASCH ANA;CERVIÑO REAL ALVARO MANUEL;ALVAREZ ENCISO PABLO;CALERO GIL CRISTINA;FERNANDEZ MOLINER SILVIA;DIAZ LOPEZ VANESA;MUÑOZ SEVERINO ROCIO PILAR. Apoderado: ALCANTARA DELGADO AYALA MARIA DEL CARMEN GEMA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 08/03/2024. Núm. 132487. T 35258, F 220, S 8, H M 104976, I/A 152
Reelecciones.
Auditor: KPMG AUDITORES SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/01/2024. Núm. 11827. T 35258, F 220, S 8, H M 104976, I/A 151
Declaración de unipersonalidad.
Cambio de identidad del socio único: ACCIONA LOGISTICA SA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 03/08/2023. Núm. 362845. T 35258, F 220, S 8, H M 104976, I/A 150
Ceses/Dimisiones.
Representan: MARTINEZ DE BARTOLOME IZQUIERDO CRISTINA.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/07/2023. Núm. 326512. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 149
Nombramientos.
Representan: MANRIQUE DE PAULA CESAR.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/07/2023. Núm. 326512. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 149
Ceses/Dimisiones.
Representan: SERRANO PEREZ DAVID.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 11/07/2023. Núm. 324746. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 148
Nombramientos.
Representan: ZABALA LOPEZ-GOMEZ MARIA DEL SOL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 11/07/2023. Núm. 324746. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 148
Reelecciones.
Auditor: KPMG AUDITORES SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/11/2022. Núm. 490129. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 147
Reelecciones.
Auditor: KPMG AUDITORES SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 17/02/2022. Núm. 83331. T 35258, F 219, S 8, H M 104976, I/A 146
Revocaciones.
Apoderado: DE LA NATIVIDAD ESCUDERO JAVIER.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 16/03/2021. Núm. 137096. T 35258, F 218, S 8, H M 104976, I/A 145
Nombramientos.
Apoderado: BERNAL AREVALO PABLO.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 29/01/2021. Núm. 57160. T 35258, F 218, S 8, H M 104976, I/A 144
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 22/01/2021. Núm. 45108. T 35258, F 217, S 8, H M 104976, I/A 143
Reelecciones.
Auditor: KPMG AUDITORES SL.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 12/11/2020. Núm. 402991. T 35258, F 217, S 8, H M 104976, I/A 142
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
5 de octubre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de Lapuente Sastre Francisco Javier
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/10/2020. Núm. 344829. T 35258, F 217, S 8, H M 104976, I/A 141
Nombramientos.
Con fecha
5 de octubre de 2020 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Martinez De Bartolome Izquierdo Cristina
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 05/10/2020. Núm. 344829. T 35258, F 217, S 8, H M 104976, I/A 141
Ampliación de capital.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 20.674,40 € el capital
social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 3.41 %, dejando el capital social de la sociedad en 627.684,40€.
Capital social anterior:
607.010 €
Aumento de capital:
20.674,40 €
Capital social resultante:
627.684,40 €
% incremento:
3.41 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/01/2020. Núm. 58960. T 35258, F 216, S 8, H M 104976, I/A 139
Modificaciones estatutarias.
Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 31/01/2020. Núm. 58960. T 35258, F 216, S 8, H M 104976, I/A 139
Cambio de domicilio social.
Traslado del domicilio social de la empresa situado en SUIZA, 18 20 C DE TRANSPORTES DE COSLADA. 28820 COSLADA. (MADRID) siendo el nuevo domicilio situado en AVDA DE ARAGON 402 - 8ª PLANTA, EDIFICIO ALLENDE (MADRID).
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 26/12/2019. Núm. 1916. T 35258, F 216, S 8, H M 104976, I/A 138
Ampliación de capital.
Los socios o accionistas de la empresa han ampliado en 6.010 € el capital
social de la sociedad. Esta ampliación incrita en el Registro Mercantil, incrementa el capital social en un 1.00 %, dejando el capital social de la sociedad en 607.010€.
Capital social anterior:
601.000 €
Aumento de capital:
6.010 €
Capital social resultante:
607.010 €
% incremento:
1.00 %
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 10/06/2019. Núm. 261108. T 35258, F 215, S 8, H M 104976, I/A 136
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
10 de junio de 2019 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de Roldan Montaud Javier
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 10/06/2019. Núm. 261109. T 35258, F 215, S 8, H M 104976, I/A 137
Nombramientos.
Con fecha
10 de junio de 2019 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Serrano Perez David
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 10/06/2019. Núm. 261109. T 35258, F 215, S 8, H M 104976, I/A 137
Nombramientos.
Con fecha
2 de enero de 2019 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de De La Natividad Escudero Javier
como
Apoderado de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 02/01/2019. Núm. 8034. T 35258, F 214, S 8, H M 104976, I/A 135
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
9 de octubre de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de Jimenez Serrano Ramon
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 09/10/2018. Núm. 420299. T 35258, F 214, S 8, H M 104976, I/A 134
Nombramientos.
Con fecha
9 de octubre de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Roldan Montaud Javier
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 09/10/2018. Núm. 420299. T 35258, F 214, S 8, H M 104976, I/A 134
Ceses/Dimisiones.
Con fecha
9 de octubre de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil
el cese o dimisión de Rodriguez Borges Tomas
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 09/10/2018. Núm. 418733. T 35258, F 214, S 8, H M 104976, I/A 133
Nombramientos.
Con fecha
9 de octubre de 2018 se inscribe en el Registro Mercantil
el nombramiento de Lapuente Sastre Francisco Javier
como
Representante de la sociedad.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil Fecha inscripción: 09/10/2018. Núm. 418733. T 35258, F 214, S 8, H M 104976, I/A 133
Nombramientos.
Publicación en el BORME de los siguientes nombramientos:
ACCIONA FORWARDING SA inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. y con domicilio en CosladaSu clasificación nacional de actividades económicas es Otras actividades anexas al transporte.
capital social de la empresa es de 627.684,40 euros y tiene una facturación anual superior a 2.500.000 euros.
ACCIONA FORWARDING SA tiene 36 cargos directivos en activo y 55 cargos directivos históricos.